PART I / PARTIE I

Download Report

Transcript PART I / PARTIE I

PART I / PARTIE I
Volume 35, No. 8 / Volume 35, no 8
Yellowknife, Northwest Territories / Territoires du Nord-Ouest
2014-08-29
ISSN 0225-5898 (Print / texte imprimé)
ISSN 2291-0409 (Online / en ligne)
NOTICE
AVIS
The full text of an appointment may be viewed at the
Office of the Registrar of Regulations, 4th floor
Courthouse, Yellowknife, NT X1A 2L9.
Le texte intégral d’une nomination peut être examiné au
bureau du registraire des règlements, Palais de Justice,
4e étage, Yellowknife (NT) X1A 2L9.
APPOINTMENTS / NOMINATIONS
Appointee/Titulaire
Address/Adresse
Registration No./
No d’enregistrement
Term/
Durée du mandat
Effective Date/
Date d’entrée
en fonctions
As a Child Protection Worker for the Northwest Territories under the Child and Family Services Act:
Préposée à la protection de l’enfance des Territoires du Nord-Ouest en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la
famille :
LAKE, Tasha
Fort Smith
A-362-2014
from/de 2014-07-11
to/à 2014-08-22
2014-07-11
As members of the Sahtu Health and Social Services Authority under the Hospital Insurance and Health and Social
Services Administration Act:
Membres de l’Administration des services de santé et des services sociaux de Sahtu en vertu de la Loi sur
l’assurance-hospitalisation et l’administration des services de santé et des services sociaux :
MCDONALD, Margaret
MCNEELY, Alphonsine
SQUIRREL, Helen
Norman Wells
Fort Good Hope
Tulita
A-353-2014
A-354-2014
A-368-2014
169
3 years/3 ans
3 years/3 ans
3 years/3 ans
2014-06-30
2014-06-30
2014-06-30
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Appointee/Titulaire
Address/Adresse
Registration No./
No d’enregistrement
Volume 35, No. 8 / Volume 35, no 8
Term/
Durée du mandat
Effective Date/
Date d’entrée
en fonctions
As an issuer of marriage licences under the Marriage Act:
Délivreuse de licences de mariage en vertu de la Loi sur le mariage :
BROWNING, Rosie
Hay River
A-369-2014
2014-07-28
As chairperson of the Inuvik Housing Authority under the Northwest Territories Housing Corporation Act:
Présidente de l’Office d’habitation d’Inuvik en vertu de la Loi sur la Société d’habitation des Territoires du
Nord-Ouest :
MCKAY-SATURNINO, Eileen
Francis
Inuvik
A-367-2014
from/de 2014-06-01
to/à 2015-11-04
2014-06-01
As a member of the Behchokö Kö Gha K’àodèe under the Northwest Territories Housing Corporation Act:
Membre de Behchokö Kö Gha K’àodèe en vertu de la Loi sur la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest :
WEDZIN, Louisa
Behchokö
A-363-2014
from/de 2014-06-02
to/à 2017-05-14
2014-06-02
As members of the Hay River Housing Authority under the Northwest Territories Housing Corporation Act:
Membres de l’Office d’habitation de Hay River en vertu de la Loi sur la Société d’habitation des Territoires du NordOuest :
BENNETT, Wayne
Hay River
A-364-2014
LAROCQUE, Melvin H.
Hay River
A-366-2014
from/de 2014-07-01
to/à 2017-06-30
from/de 2014-07-01
to/à 2017-06-30
2014-07-01
2014-07-01
As vice-chairperson of the Hay River Housing Authority under the Northwest Territories Housing Corporation Act:
Vice-présidente de l’Office d’habitation de Hay River en vertu de la Loi sur la Société d’habitation des Territoires du
Nord-Ouest :
BOUCHARD, Leslie Kathleen
Hay River
A-365-2014
from/de 2014-06-01
to/à 2015-12-04
2014-06-01
As a public health officer under the Public Health Act:
Administratrice de la santé publique en vertu de la Loi sur la santé publique :
CHENG, Lydia
Yellowknife
A-352-2014
from/de 2014-07-15
to/à 2014-12-20
2014-07-15
As a Social Welfare Officer for the Northwest Territories under the Social Assistance Act:
Agente du bien-être social des Territoires du Nord-Ouest en vertu de la Loi sur l’assistance sociale :
SATURNINO, Jolene
Yellowknife
A-355-2014
2014-07-15
As chairperson of the Victims Assistance Committee under the Victims of Crime Act:
Présidente du Comité d’aide aux victimes en vertu de la Loi sur les victimes d’actes criminels :
LAROCQUE, Bridget
Inuvik
A-359-2014
170
from/de 2014-08-01
to/à 2017-07-31
2014-08-01
Part I / Partie I
Volume 35, No. 8 / Volume 35, no 8
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Appointee/Titulaire
Address/Adresse
Registration No./
No d’enregistrement
Term/
Durée du mandat
Effective Date/
Date d’entrée
en fonctions
As a member of the Victims Assistance Committee under the Victims of Crime Act:
Membre du Comité d’aide aux victimes en vertu de la Loi sur les victimes d’actes criminels :
LAROCQUE, Bridget
Inuvik
A-358-2014
from/de 2014-08-01
to/à 2017-07-31
2014-08-01
As an officer under the Waste Reduction and Recovery Act:
Agente d’exécution en vertu de la Loi sur la réduction et la récupération des déchets :
BECK, Heather Elaine
Yellowknife
A-356-2014
2014-07-15
As a wildlife guardian under the Wildlife Act:
Garde-chasse en vertu de la Loi sur la faune :
HICKLING, Keith Morley
Hershel
Norman Wells
A-351-2014
from/de 2014-06-16
to/à 2014-10-20
2014-06-16
As a wildlife officer under the Wildlife Act:
Agente de la faune en vertu de la Loi sur la faune :
BECK, Heather Elaine
Yellowknife
A-357-2014
2014-07-15
As members of the Norman Wells Youth Justice Committee under the Youth Justice Act and Youth Criminal Justice Act
(Canada):
Membres du comité de justice pour la jeunesse de Norman Wells en vertu de la Loi sur le système de justice pour les
adolescents et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) :
ERB, Myles
LEBEL, Camille
Norman Wells
Norman Wells
A-360-2014
A-361-2014
3 years/3 ans
3 years/3 ans
2014-07-16
2014-07-16
REVOCATIONS / RÉVOCATIONS
Name/Nom
Effective Date/
Date d’entrée
en fonctions
Revocation No./
No de révocation
Original Appointment/
Première nomination
CHILD AND FAMILY SERVICES ACT - Child Protection Workers for the Northwest Territories
LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE - préposés à la protection de l’enfance des Territoires
du Nord-Ouest
COPELOWITZ, Larry
JACKSON, Elizabeth
AR-158-2014
AR-159-2014
2014-06-01
2014-07-04
171
A-063-2014
A-989-98
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Name/Nom
Revocation No./
No de révocation
Volume 35, No. 8 / Volume 35, no 8
Effective Date/
Date d’entrée
en fonctions
Original Appointment/
Première nomination
HOSPITAL INSURANCE AND HEALTH AND SOCIAL SERVICES ADMINISTRATION ACT - inspector and auditor
LOI SUR L’ASSURANCE-HOSPITALISATION ET L’ADMINISTRATION DES SERVICES DE SANTÉ ET DES
SERVICES SOCIAUX - inspecteur et vérificateur
ROBERTSON, Scott
AR-160-2014
2014-07-15
A-335-2008
2014-07-09
A-028-2014
JUDICATURE ACT - deputy Sheriff
LOI SUR L’ORGANISATION JUDICIAIRE - Shérif adjoint
JACKSON, Daniel William
AR-157-2014
NORTHWEST TERRITORIES HOUSING CORPORATION ACT - member of the Behchokö Kö Gha K’àodèe
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST - membre de Behchokö Kö Gha
K’àodèe
WEDZIN, Louise
AR-161-2014
2014-06-01
A-298-2014
NORTHWEST TERRITORIES HOUSING CORPORATION ACT - vice-chairperson of the Hay River Housing
Authority
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST - vice-président de l’Office
d’habitation de Hay River
DEWAR, John Stuart
AR-162-2014
2014-05-31
A-493-2013
SOCIAL ASSISTANCE ACT - Social Welfare Officers for the Northwest Territories
LOI SUR L’ASSISTANCE SOCIALE - agentes du bien-être social des Territoires du Nord-Ouest
REBESCA, Holly
RUSSELL, Jolene
AR-153-2014
AR-154-2014
2014-06-12
2014-07-14
A-263-2009
A-431-2008
AR-156-2014
2014-06-30
A-056-2007
AR-155-2014
2014-07-15
A-293-2014
TERRITORIAL COURT ACT - deputy territorial judge
LOI SUR LA COUR TERRITORIALE - juge territorial adjoint
PHILP, The Hon. / L’hon.
Robert A.
WILDLIFE ACT - wildlife guardian
LOI SUR LA FAUNE - garde-chasse
BECK, Heather
172
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Volume 35, No. 8 / Volume 35, no 8
GOVERNMENT NOTICES (REGISTRIES) / AVIS DU GOUVERNEMENT (BUREAUX D’ENREGISTREMENT)
BUSINESS CORPORATIONS ACT
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
NOTICES OF INCORPORATION OF TERRITORIAL CORPORATIONS (section 8):
AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS TERRITORIALES (article 8) :
Corporation/
Société par actions
Corporation No./
No de la société par actions
Registered Office/
Bureau enregistré
Date of Incorporation/
Date de la constitution
506782 N.W.T. LTD.
506782
Suite 601
4920 52nd Street
Yellowknife NT
X1A 3T1
2014-07-10
506783 N.W.T. LTD.
506783
5107 53rd Street
P.O. Box 2910
Yellowknife NT
X1A 2R2
2014-07-15
JESMIC HOLDINGS
LTD.
506784
YK Centre East
200-4915 48th Street
P.O. Box 818
Yellowknife NT
X1A 2N6
2014-07-15
PETANÉA
CORPORATION
506785
5107 53rd Street
P.O. Box 2910
Yellowknife NT
X1A 2R2
2014-07-17
DIVERSIFIED
CONSTRUCTION
LTD.
506786
5107 53rd Street
P.O. Box 2910
Yellowknife NT
X1A 2R2
2014-07-17
JACKFISH
BREWERY INC.
506787
5107 53rd Street
P.O. Box 2910
Yellowknife NT
X1A 2R2
2014-07-21
KATLOTECH
COMMUNICATIONS LTD.
506788
Wolf Drive 253
P.O. Box 3021
Hay River Reserve NT
X0E 1G4
2014-07-24
3 KINGS
DEVELOPMENT
GROUP INC.
506789
203-48 Con Road
Yellowknife NT
X1A 1X6
2014-07-30
YELLOWKNIFE
NORTHERN
LIGHTS TOUR
INC.
506790
6204 Finlayson Drive
Yellowknife NT
X1A 3G9
2014-07-30
173
Part I / Partie I
Volume 35, No. 8 / Volume 35, no 8
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
RARE EARTH
PRODUCTIONS
INC.
506791
6197 Finlayson Drive
Yellowknife NT
X1A 3K9
2014-07-30
THE ARCTIC
WATER
COMPANY INC.
506792
301-5109 48th Street
Yellowknife NT
X1A 1N5
2014-08-08
CP REIT NWT
PROPERTIES
LIMITED
506793
Suite 601
4920 52nd Street
Yellowknife NT
X1A 3T1
2014-08-11
HARDROCK
RESOURCES LTD.
506794
5107 53rd Street
P.O. Box 2910
Yellowknife NT
X1A 2R2
2014-08-13
NOTICES OF CHANGE OF NAME OF TERRITORIAL CORPORATIONS [subsections 179(2) and 13(4)]:
AVIS DE CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS TERRITORIALES
[paragraphes 179(2) et 13(4)] :
Former Name/
Ancienne dénomination
sociale
Corporation No./
No de la société par actions
New Name/
Nouvelle dénomination
sociale
Date of Change/
Date du changement
506597 N.W.T. LTD.
506597
NBS CONTRACTING
LTD.
2014-08-18
506628 N.W.T. LTD.
506628
END OF THE ROAD
LTD.
2014-07-08
SYNERGIC
ACCOUNTING
PROFESSIONAL
CORPORATION
506673
EPR YELLOWKNIFE
ACCOUNTING
PROFESSIONAL
CORPORATION
2014-07-15
NOTICES OF AMENDMENT OF ARTICLES OF TERRITORIAL CORPORATIONS [subsection 29(6) or section 180]:
AVIS DE MODIFICATION DES STATUTS DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS TERRITORIALES [paragraphe 29(6) ou
article 180] :
Corporation/
Société par actions
Corporation No./
No de la société par actions
Date of Amendment/
Date de la modification
923239 N.W.T. LTD.
503239
2014-07-23
NBS CONTRACTING LTD.
506597
2014-08-18
END OF THE ROAD LTD.
506628
2014-07-08
EPR YELLOWKNIFE
ACCOUNTING
PROFESSIONAL
CORPORATION
506673
2014-07-15
174
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
506715 N.W.T. LTD.
506715
Volume 35, No. 8 / Volume 35, no 8
2014-07-08
NOTICES OF REVIVAL OF TERRITORIAL CORPORATIONS [subsection 210(3)]:
AVIS DE RECONSTITUTION DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS TERRITORIALES [paragraphe 210(3)] :
Corporation/
Société par actions
Corporation No./
No de la société par actions
Date of Revival/
Date de la reconstitution
NORTHERN FLAIR LTD.
500352
2014-07-04
TETLIT PETROLEUM
DISTRIBUTION INC.
504826
2014-08-06
ABORIGINAL CONTRACTORS
CORPORATION
505406
2014-07-11
NOTICES OF DISSOLUTION OF TERRITORIAL CORPORATIONS [subsection 212(5)]:
AVIS DE DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS TERRITORIALES [paragraphe 212(5)] :
Corporation/
Société par actions
Corporation No./
No de la société par actions
Date of Dissolution/
Date de la dissolution
JAVAROMA GOURMET
COFFEE & TEA LTD.
503589
2014-08-12
JACALYN ENTERPRISES LTD.
503733
2014-07-04
BEAUFORT
ENVIRONMENTAL
TECHNOLOGIES INC.
505388
2014-07-09
ECA CONSTRUCTION LTD.
505918
2014-08-08
506456 N.W.T. LTD.
506456
2014-08-08
NOTICES OF INTENT TO DISSOLVE TERRITORIAL CORPORATIONS [subsections 214(2), 214(3), 214(4) or
214(5)]:
AVIS D’INTENTION DE DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS TERRITORIALES [paragraphes 214(2),
214(3), 214(4) ou 214(5)] :
Corporation/
Société par actions
Corporation No./
No de la société par actions
Date of Notice/
Date de l’avis
NEHKEDI ENVIRONMENTAL
LTD.
505864
2014-06-03
6221 NWT LTD.
506221
2014-06-12
BRANT CONTRACTING
GROUP LTD.
505911
2014-07-04
JOFRAN ENTERPRISES LTD.
500742
2014-07-07
QUYTA HOLDINGS LTD.
500774
2014-07-07
175
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Volume 35, No. 8 / Volume 35, no 8
C. HEAL CONSTRUCTION
LTD.
501399
2014-07-07
MCL ENTERPRISES LTD.
501839
2014-07-07
C.H. HOLDINGS LTD.
502376
2014-07-07
SPIRITWALKER LTD.
502448
2014-07-07
SMALL BUSINESS GROUP
LTD. (THE)
502653
2014-07-07
OTTER ENTERPRISES LTD.
502902
2014-07-07
NORTH TRUCKING LTD.
503090
2014-07-07
DOLYNNY PHARMACY
HOLDINGS LTD.
503167
2014-07-07
ATB CONSTRUCTION LTD.
503362
2014-07-07
FLOYD HOLDINGS LTD.
503399
2014-07-07
YAMORIA GROCERY LTD.
503464
2014-07-07
L.D. AIR LEASING LTD.
503515
2014-07-07
DELINE CONSTRUCTION
LTD.
503727
2014-07-07
CASCADE
COMMUNICATIONS LTD.
503934
2014-07-07
964040 N.W.T. LTD.
504040
2014-07-07
TUMITCHIAT OUTFITTERS
LTD.
504230
2014-07-07
SAHTU OIL INCORPORATED
504400
2014-07-07
ARSLANIAN CUTTING
WORKS (NWT) LTD.
504418
2014-07-07
994461 N.W.T. LTD.
504461
2014-07-07
994541 N.W.T. LTD.
504541
2014-07-07
F.E.D. TILE LTD.
504561
2014-07-07
HARLOR ENTERPRISES LTD.
504617
2014-07-07
4733 N.W.T. LTD.
504733
2014-07-07
TLI CHO EXPLOSIVES
LIMITED
504798
2014-07-07
176
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Volume 35, No. 8 / Volume 35, no 8
HAYLOR FINANCIAL
SERVICES LTD.
504850
2014-07-07
ROBERT CONCEPTS
HOLDINGS LTD.
504889
2014-07-07
COLD MOUNTAIN
COMPUTING INC.
505005
2014-07-07
KIGGIAK-EBA CONSULTING
LTD.
505067
2014-07-07
NU IMAGE CONSTRUCTION
LTD.
505093
2014-07-07
DARGO AND ASSOCIATES
LTD.
505113
2014-07-07
5119 N.W.T. LTD.
505119
2014-07-07
NEHTRUH-EBA CONSULTING
LTD.
505121
2014-07-07
DEH CHO BRIDGE
CORPORATION LTD.
505132
2014-07-07
V.P. VENTILATION &
PLUMBING LTD.
505204
2014-07-07
5227 N.W.T. LTD.
505227
2014-07-07
HEAD GEAR LTD.
505289
2014-07-07
GENE'S PAINTING &
DRYWALLING LTD.
505306
2014-07-07
S.R.P. PETROLEUM LTD.
505315
2014-07-07
POLAR RESOURCE SERVICES
LTD.
505345
2014-07-07
MG LODGING INUVIK LTD.
505412
2014-07-07
5454 N.W.T. LTD.
505454
2014-07-07
5456 N.W.T. INC.
505456
2014-07-07
5562 NWT INC.
505562
2014-07-07
5571 N.W.T. LIMITED
505571
2014-07-07
NLC HOLDINGS LTD.
505633
2014-07-07
JANOR SERVICES INC.
505634
2014-07-07
CLEMCO LTD.
505635
2014-07-07
177
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Volume 35, No. 8 / Volume 35, no 8
5682 N.W.T. LTD.
505682
2014-07-07
DOMES CONSTRUCTION LTD.
505723
2014-07-07
T & M WELDING LTD.
505777
2014-07-07
5786 N.W.T. LTD.
505786
2014-07-07
NORTH OF 60 HAULER LTD.
505818
2014-07-07
NORTH FITNESS GROUP LTD.
505832
2014-07-07
5845 N.W.T. LTD.
505845
2014-07-07
5853 N.W.T. LTD.
505853
2014-07-07
5885 NWT INC.
505885
2014-07-07
5930 NWT LTD.
505930
2014-07-07
PIONEER SOLUTIONS LTD.
505931
2014-07-07
BARKER ENTERPRISES LTD.
505944
2014-07-07
PADINKA INCORPORATED
505989
2014-07-07
BAILES FAMILY SALES AND
SERVICE LTD.
506043
2014-07-07
DAS ENTERPRISES INC.
506083
2014-07-07
6098 N.W.T. LTD.
506098
2014-07-07
UPUN-LGL LIMITED
506115
2014-07-07
TI K'EDEH ENTERPRISES
LIMITED
506145
2014-07-07
DETON'CHO PURE
ELEMENTS LTD.
506188
2014-07-07
MOJO INCORPORATED
506326
2014-07-07
FREEDOM NORTH INC.
506340
2014-07-07
6345 N.W.T. LTD.
506345
2014-07-07
LESKIW SERVICES INC.
506346
2014-07-07
MCCAGG CONSULTING &
MANAGEMENT INC.
506347
2014-07-07
NORWEGIAN INDUSTRIES
LTD.
506348
2014-07-07
TLICHO-VENTURE INC.
506350
2014-07-07
178
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Volume 35, No. 8 / Volume 35, no 8
6354 N.W.T. LIMITED
506354
2014-07-07
MUSCLEHEADS INC.
506359
2014-07-07
SM CONTRACTING LTD.
506363
2014-07-07
6366 N.W.T. INC.
506366
2014-07-07
CURB APPEAL LTD.
506367
2014-07-07
CHAMPA-CANADA
DEVELOPMENT
CORPORATION
506372
2014-07-07
GW ELECTRIC AND
MACHINE LTD.
506390
2014-07-07
6395 N.T. INC.
506395
2014-07-07
6399 N.W.T. LTD.
506399
2014-07-07
6400 N.W.T. LTD.
506400
2014-07-07
6403 N.W.T. LTD.
506403
2014-07-07
GOTÍNE ENVIRONMENTAL
LTD.
506406
2014-07-07
DECKER INSURANCE
SERVICES LTD.
506413
2014-07-07
DET'ON CHO EARTH
ENERGY LTD.
506425
2014-07-07
DET'ON CHO RYFAN LTD.
506426
2014-07-07
WHAEDO NAAWO INC.
506431
2014-07-07
ROBIN FOREST
CONTRACTOR INC.
506432
2014-07-07
506435 N.W.T. LTD.
506435
2014-07-07
ARENGA VEGA VENTURES
LTD.
506436
2014-07-07
506439 N.W.T. LTD.
506439
2014-07-07
506441 N.W.T. LTD.
506441
2014-07-07
506442 NORTHWEST
TERRITORIES INC.
506442
2014-07-07
MG LODGING INUVIK LTD.
505412
2014-07-15
994461 N.W.T. LTD.
504461
2014-07-16
179
Part I / Partie I
Volume 35, No. 8 / Volume 35, no 8
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
TEE JAY CONTRACTING INC.
505329
2014-07-24
NOTICES OF DISSOLUTION OF TERRITORIAL CORPORATIONS [subsection 214(6)]:
AVIS DE DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS TERRITORIALES [paragraphe 214(6)] :
Corporation/
Société par actions
Corporation No./
No de la société par actions
Date of Dissolution/
Date de la dissolution
CAMILLUS ENGINEERING
CONSULTANTS LTD.
502750
2014-08-08
NOTICES OF REGISTRATION OF EXTRA-TERRITORIAL CORPORATIONS [subsection 285(1)]:
AVIS D’ENREGISTREMENT DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS EXTRATERRITORIALES [paragraphe 285(1)] :
Corporation/
Société par actions
Corporation No./
No de la société
par actions
Registered Office/
Bureau enregistré
Jurisdiction/
Autorité législative
Date of Registration/
Date de l’enregistrement
FENIX OUTDOOR
IMPORT LLC
611268
Suite 601
4920 52nd Street
Yellowknife NT
X1A 3T1
Delaware
2014-07-03
MOTT
MACDONALD
CANADA
LIMITED / MOTT
MACDONALD
CANADA LIMITÉE
611269
Suite 601
4920 52nd Street
Yellowknife NT
X1A 3T1
Ontario
2014-07-08
RAYTHEON
CANADA
LIMITED /
RAYTHEON
CANADA LIMITÉE
611270
205-5105 50th Street
Yellowknife NT
X1A 1S1
Canada
2014-07-10
LALONDE & SON
CORP.
611272
205-5105 50th Street
Yellowknife NT
X1A 1S1
Alberta
2014-07-10
SEMA RAILWAY
STRUCTURES
INC.
611274
Suite 601
4920 52nd Street
Yellowknife NT
X1A 3T1
Canada
2014-07-17
ALSTOM POWER
CANADA INC. /
ALSTOM
ÉNERGIE
CANADA INC.
611276
Suite 601
4920 52nd Street
Yellowknife NT
X1A 3T1
Canada
2014-07-18
DOTERRA
CANADA, ULC
611278
Suite 601
4920 52nd Street
Yellowknife NT
X1A 3T1
British Columbia
2014-07-23
180
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Volume 35, No. 8 / Volume 35, no 8
MAC FINANCIAL
RECOVERY
(CANADA) INC.
611279
Suite 802
Northwest Tower
5201 50th Avenue
Yellowknife NT
X1A 3S9
Canada
2014-07-23
CDC CONSULTING
SERVICES INC.
611280
Suite 601
4920 52nd Street
Yellowknife NT
X1A 3T1
Alberta
2014-07-29
LK-RCS RESOURCE
SERVICES LTD.
611281
112 Sunset Blvd.
P.O. Box 76
Łutselk’e NT \
X0E 1A0
Alberta
2014-07-31
IMKT DIRECT
SOLUTIONS
CORPORATION
611282
YK Centre East
200-4915 48th Street
P.O. Box 818
Yellowknife NT
X1A 2N6
British Columbia
2014-07-31
B+H ARCHITECTS
INC.
611284
Suite 601
4920 52nd Street
Yellowknife NT
X1A 3T1
British Columbia
2014-08-06
PEACE COUNTRY
OILFIELD
CONTRACTORS
LTD.
611285
Suite 601
4920 52nd Street
Yellowknife NT
X1A 3T1
Alberta
2014-08-07
HYUNDAI CAPITAL
CANADA INC.
611286
Suite 601
4920 52nd Street
Yellowknife NT
X1A 3T1
Canada
2014-08-08
CANADA
BROKERLINK
INC.
611288
Suite 601
4920 52nd Street
Yellowknife NT
X1A 3T1
Alberta
2014-08-11
FORMULA
CONTRACTORS
B.C. LTD.
611290
5016 47th Street
P.O. Box 383
Yellowknife NT
X1A 2N3
British Columbia
2014-08-12
8844747 CANADA
INC.
611292
YK Centre East
200-4915 48th Street
P.O. Box 818
Yellowknife NT
X1A 2N6
Canada
2014-08-14
8742995 CANADA
INC.
611293
YK Centre East
200-4915 48th Street
P.O. Box 818
Yellowknife NT
X1A 2N6
Canada
2014-08-14
181
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
MASTEC
TRANSMISSION
SERVICES
CANADA LTD.
611295
Suite 601
4920 52nd Street
Yellowknife NT
X1A 3T1
Volume 35, No. 8 / Volume 35, no 8
Alberta
2014-08-15
NOTICES OF CHANGE OF NAME OF EXTRA-TERRITORIAL CORPORATIONS [subsection 289(4)]:
AVIS DE CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
EXTRATERRITORIALES [paragraphe 289(4)] :
Name of Corporation/
Dénomination sociale
de la société par actions
Corporation No./
No de la société par actions
New Name of Corporation/
Nouvelle dénomination
sociale de la société par
actions
Effective Date/
Date de prise d’effet
GWICHA GWICH'IN
COUNCIL
605284
GWICHYA GWICH'IN
COUNCIL
2014-06-27
NATIONAL BANK
SECURITIES
INC. / PLACEMENTS
BANQUE
NATIONALE INC.
609612
BANQUE NATIONALE
INVESTISSEMENTS
INC. / NATIONAL
BANK
INVESTMENTS INC.
2014-05-12
9301-1161 QUÉBEC
INC.
611243
SÉCURIGLOBE INC.
2014-06-09
NOTICES OF AMALGAMATION OF EXTRA-TERRITORIAL CORPORATIONS [subsection 290(2)]:
AVIS DE FUSION DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS EXTRATERRITORIALES [paragraphe 290(2)] :
Corporation/
Société par actions
Corporation No./
No de la société
par actions
Amalgamating Corporations/
Sociétés par actions fusionnées
Date of Amalgamation/
Date de la fusion
CANWEL
BUILDING
MATERIALS
LTD.
611271
609295: QUINCAILLERIE CANWEL
INC. / CANWEL HARDWARE INC.;
610510: CANWEL BUILDING
MATERIALS LTD.
2011-01-01
CGI
INFORMATION
SYSTEMS AND
MANAGEMENT
CONSULTANTS
INC. /
CONSEILLERS
EN SYSTÈMES
D’INFORMATION ET EN
GESTION CGI
INC.
611273
608846: CGI INFORMATION
SYSTEMS AND MANAGEMENT
CONSULTANTS
INC. / CONSEILLERS EN
SYSTÈMES D’INFORMATION ET
EN GESTION CGI INC.; LOGICA
BUSINESS TECHNOLOGY CORP.
2012-10-01
182
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Volume 35, No. 8 / Volume 35, no 8
BUREAU VERITAS
COMMODITIES
CANADA LTD.
611275
609629: ACME ANALYTICAL
LABORATORIES (VANCOUVER)
LTD.; 608231: ACME ANALYTICAL
LABORATORIES LTD.; BUREAU
VERITAS COMMODITIES
CANADA LTD.; INSPECTORATE
EXPLORATION & MINING
SERVICES LTD.
2014-07-01
SYSCO CANADA,
INC.
611277
611015: SYSCO CANADA, INC.;
SYSCO HOLDINGS LIMITED ;
SYSCO CANADA NS, LIMITED;
SYSCO CENTRAL ONTARIO, INC.;
SYSCO HOLDINGS OF B.C., INC.;
SYSCO VICTORIA, INC.;
SYSCO HOLDINGS OF KELOWNA,
INC.; SYSCO KELOWNA LTD.
2014-06-29
ELEMENT FLEET
MANAGEMENT
II INC.
611283
604699: PHH VEHICLE
MANAGEMENT SERVICES INC. /
PHH SERVICES DE GESTION DE
VEHICULES INC.; 8903719
CANADA INC.
2014-07-07
ALUMA SYSTEMS
INC.
611287
609953: ALUMA SYSTEMS INC.;
BULLSEYE CANADA
ACQUISITION, B.C. LTD.;
BULLSEYE CANADA
INFRASTRUCTURE ULC
2014-02-01
CANOE
FINANCIAL
CORP.
611289
609780: RIVERSTREAM ASSET
MANAGEMENT LTD.;
610269: CANOE FINANCIAL
CORP.; CANOE CAPITAL CORP.;
ENERVEST DOVERSIFIED
RESOURCE MANAGEMENT LTD.
2014-01-01
TIGER CALCIUM
SERVICES INC.
611291
606214: TIGER CALCIUM SERVICES
INC.; 1830564 ALBERTA LTD.
2014-08-01
DILLON
CONSULTING
LIMITED / LES
CONSULTANTS
DILLON
LIMITEE
611294
610656: DILLON CONSULTING
LIMITED / LES CONSULTANTS
DILLON LIMITEE; HABITAT
WORKS! INC.; 8365989 CANADA
INC.; 8365997 CANADA INC.;
8366012 CANADA INC.; IAN
DANCE LIMITED; 8365962
CANADA INC.
2013-03-01
183
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Volume 35, No. 8 / Volume 35, no 8
NOTICES OF CANCELLATION OF REGISTRATION OF EXTRA-TERRITORIAL CORPORATIONS
[subsection 294(6)]:
AVIS D’ANNULATION DE L’ENREGISTREMENT DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS EXTRATERRITORIALES
[paragraphe 294(6)]:
Corporation/
Société par actions
Corporation No./
No de la société par actions
Date of Cancellation/
Date de l’annulation
GENSEN LAND CO. LTD.
601679
2014-08-12
C.J. EL CORP.
604606
2014-07-03
ARROW TRANSPORTATION
SYSTEMS INC.
604814
2014-07-03
KELMAN TECHNOLOGIES
INC.
605045
2014-07-03
DOGRIB NATION
DEVELOPMENT
AUTHORITY INC.
605129
2014-07-03
DOGRIB NATION HERITAGE
FOUNDATION
605178
2014-07-03
AURORA SURVEYOR LTD.
605457
2014-07-03
CHEMINÉES SÉCURITÉ
INTERNATIONAL
LTEE / SECURITY
CHIMNEYS
INTERNATIONAL LTD.
606144
2014-07-03
SA CHO DEVELOPMENTS
LTD.
606401
2014-07-03
CANANWILL CANADA
LIMITED
606417
2014-07-03
GREAT BEAR AVIATION LTD.
606605
2014-07-03
BLOCKBUSTER CANADA CO.
606659
2014-07-03
VALARD CONSTRUCTION
LTD.
606771
2014-07-03
BGRS RELOCATION CANADA
LTD.
606827
2014-07-04
BP CANADA ENERGY
RESOURCES COMPANY
606894
2014-07-04
CUSTOM CARRIERS &
OILFIELD HAULING LTD.
606959
2014-07-04
ARCTIC WINGS LTD.
607023
2014-07-04
184
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Volume 35, No. 8 / Volume 35, no 8
INTEGRATED PAYMENT
SYSTEMS CANADA
INC. / SYSTEMS INTEGRES
DE PAIMENT CANADA INC.
607288
2014-07-04
FX ALLIANCE, LLC
607416
2014-08-08
CABER FEIDH
MANAGEMENT INC.
607421
2014-07-04
HARTFORD INVESTMENTS
CANADA CORP. / LA
CORPORATION
D'INVESTISSEMENTS
HARTFORD CANADA
607537
2014-07-04
HIGHLAND NORTH INC.
607546
2014-07-09
DARLEN TRANSPORT (1986)
LTD.
607615
2014-07-04
GOLDEN BULL RESOURCES
CORPORATION
607631
2014-07-04
TEAM PIPELINE LTD.
607649
2014-07-04
DESTINY WELDING &
CONSTRUCTION LTD.
607650
2014-07-04
A.T.R. ENTERPRISES INC.
607707
2014-07-04
6030009 CANADA INC.
607778
2014-07-07
DON BYRNE INVESTMENTS
INC.
607783
2014-07-07
338 RESOURCES COMPANY
607801
2014-07-07
HYCHEM CANADA INC.
607816
2014-08-08
ANACONDA MINING INC.
608052
2014-07-07
NYTIS EXPLORATION
COMPANY INC.
608069
2014-07-07
H I W SURVEYS LTD.
608194
2014-07-07
3267911 CANADA INC.
608221
2014-07-07
326551 CANADA INC.
608222
2014-07-07
RSM RICHTER INC.
608276
2014-07-07
PRODIGY GOLD INC.
608339
2014-07-07
DELTA MIKE HOLDINGS
LTD.
608390
2014-07-07
185
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Volume 35, No. 8 / Volume 35, no 8
BIG BEAR MULCHING LTD.
608412
2014-07-07
RECOVERCORP INC.
608426
2014-07-07
SATDEO INC.
608512
2014-07-07
LIFTCAPITAL
CORPORATION /
CORPORATION
LIFTCAPITAL
608566
2014-07-07
JENNINGS CAPITAL INC.
608567
2014-07-04
PARKVALLEY CONSULTING
LTD.
608651
2014-07-07
CANADIAN ACCESS MAT
CORPORATION
608805
2014-07-07
6081576 CANADA INC.
608817
2014-07-07
BORDER LINE TRANSPORT
LTD.
608940
2014-07-07
6616038 CANADA INC.
608964
2014-07-07
FHTM CANADA INC.
608982
2014-07-07
AGEL ENTERPRISES
(CANADA) ULC
609160
2014-07-07
4010680 CANADA INC.
609200
2014-07-07
UNCOMMON JOURNEYS LTD.
609220
2014-07-07
AVEOS FLEET
PERFORMANCE INC. /
AVEOS PERFORMANCE
AERONAUTIQUE INC.
609252
2014-07-07
CIS LAND & RESOURCE
MANAGEMENT LTD.
609296
2014-07-10
WILD WELL CONTROL, INC.
609363
2014-07-10
YOURTRAVELBIZ.COM
CANADA, ULC
609368
2014-07-10
YTB TRAVEL NETWORK OF
CANADA, ULC
609383
2014-07-10
NORROCK REALTY FINANCE
G.P. INC.
609415
2014-07-10
NOR-DON COLLECTION
NETWORK INC. / LE
RESEAU NOR-DON AGENT
DE RECOUVREMENT INC.
609468
2014-07-10
186
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Volume 35, No. 8 / Volume 35, no 8
ALLEGIS LLC
609483
2014-07-10
7036795 CANADA INC.
609564
2014-07-10
UMBONO INVESTMENT AND
MANAGEMENT SERVICES
INC.
609571
2014-07-10
SOLUTIONS STAFFING INC.
609576
2014-07-10
POLAR TIRES AND LUBES
INC.
609626
2014-07-10
FIRST PINNACLE ALARM
(CANADA) INC.
609769
2014-07-10
BICKERTON BROKERS ONT.
LTD.
609835
2014-07-10
WPC RESOURCES INC.
609870
2014-07-10
COMPUTER SOFTWARE
ENGINEERING RESOURCES,
INC.
609879
2014-07-10
SHOCKEDIZZLE
ELECTRIZZLE INC.
609899
2014-07-08
PETRAN RESOURCE
MANAGEMENT LIMITED
609920
2014-07-09
1456998 ALBERTA LTD.
609932
2014-07-09
WEST RIVER HOLDINGS LTD.
609933
2014-07-09
SECURITAS CANADA LIMITED /
SECURITAS CANADA LIMITÉE
609976
2014-07-09
COLONY MANAGEMENT INC.
609984
2014-07-09
PRESTIGE TELECOM INC.
609987
2014-07-09
821951 ALBERTA LTD.
609994
2014-07-09
3234808 NOVA SCOTIA
LIMITED
609998
2014-07-09
COMAPLEX MINERALS
CORP.
610024
2014-07-09
EXPLORERS CORNER LLC
610025
2014-07-09
MYDIGNITY INC.
610110
2014-07-09
RESOLVE CORPORATION /
CORPORATION RESOLVE
610131
2014-07-09
187
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Volume 35, No. 8 / Volume 35, no 8
S & C ELECTRIC CANADA
LTD.
610135
2014-07-10
POINTS NORTH CREATIVE
INC.
610149
2014-07-10
DEH GAH BRIDGE LTD.
610168
2014-07-10
BP CANADA ENERGY
COMPANY
610205
2014-07-08
FILTER INNOVATIONS INC.
610215
2014-07-08
MITCHELMORE
ENGINEERING COMPANY
LTD.
610236
2014-07-08
ALTAGAS HOLDINGS INC.
610243
2014-07-08
CONCREATE USL (GP) INC.
610254
2014-07-08
ANDESITE CAPITAL, L.L.C.
610272
2014-07-09
REMOTE PREFAB HOMES
INC.
610273
2014-07-08
NIRRIE KISTAN-GOPIE &
ASSOCIATES INC.
610290
2014-07-08
KEN GIBERSON TRANSPORT
LTD.
610292
2014-07-08
WORD TO THE WALL INC.
610309
2014-07-08
LIBERTY SECURITY
SYSTEMS INC.
610334
2014-07-18
ASCENDANT SECURITIES
INC.
610347
2014-07-08
7074875 CANADA INC.
610348
2014-07-08
TUNDRA PROCESS
SOLUTIONS LTD.
610357
2014-07-08
CANADIAN MINE SERVICES
INC.
610379
2014-07-08
2011031 ONTARIO INC.
610388
2014-07-08
SYL'S MECHANICAL
COMPANY LTD.
610426
2014-07-08
SUMMIT 1998 OILFIELD LTD.
610464
2014-07-08
INRUSH AUTOMATION &
TECHNOLOGIES INC.
610507
2014-07-08
188
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Volume 35, No. 8 / Volume 35, no 8
SANDMAN CONSTRUCTION
INC.
610517
2014-07-08
WILFRID LAURIER
UNIVERSITY
610614
2014-07-08
BRIAN J. BRENDZAN
PROFESSIONAL
CORPORATION
610632
2014-07-08
AKCL INVESTMENTS LTD.
610660
2014-07-08
JETWASH AVIATION
SERVICES LTD.
610663
2014-07-10
BROOKFIELD GLOBAL
RELOCATION SERVICES
LIMITED / SERVICES
GLOBAUX DE
RELOGEMENT
BROOKFIELD LIMITEE
610714
2014-07-08
NABORS WELL SERVICES
CANADA LTD.
611094
2014-07-25
NOTICES OF REINSTATEMENT OF REGISTRATION OF EXTRA-TERRITORIAL CORPORATIONS
[subsection 295(2)]:
AVIS DE REMISE EN VIGUEUR DE L’ENREGISTREMENT DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
EXTRATERRITORIALES [paragraphe 295(2)]:
Corporation/
Société par actions
Corporation No./
No de la société par actions
Date of Reinstatement/
Date de la remise en vigueur
PHH VEHICLE
MANAGEMENT SERVICES
INC. / PHH SERVICES DE
GESTION DE VEHICULES
INC.
604699
2014-08-01
SOCIETIES ACT
LOI SUR LES SOCIÉTÉS
NOTICES OF INCORPORATION OF SOCIETIES [subsection 4(4)]:
AVIS DE CONSTITUTION EN PERSONNE MORALE [paragraphe 4(4)] :
Name/
Dénomination sociale
Incorporation No./
No de constitution
Location of Operations/
Lieu d'exercice des
activités
Incorporation Date/
Date de constitution
TUKTOYAKTUK MUSIC
FESTIVAL
COMMITTEE
701934
Tuktoyaktuk
2014-07-18
FAST EDDY'S BALL
TEAM
701935
Fort Resolution
2014-08-08
189
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
THE INUVIK
EMERGENCY
WARMING CENTRE
SOCIETY
701936
Volume 35, No. 8 / Volume 35, no 8
Inuvik
2014-08-08
NOTICES OF DISSOLUTION OF SOCIETIES (section 27):
AVIS DE DISSOLUTION D'UNE SOCIÉTÉ (article 27) :
Name/
Dénomination sociale
Incorporation No./
No de constitution
Dissolution Date/
Date de dissolution
CANADIAN MENTAL HEALTH
ASSOCIATION, INUVIK
BRANCH
700650
2014-08-08
TE PEE HOUSING
ASSOCIATION
700847
2014-08-08
INUVIK CHILD
DEVELOPMENT
CENTRE
701154
2014-07-08
GOVERNMENT NOTICES (MISCELLANEOUS) / AVIS DU GOUVERNEMENT (DIVERS)
NOTICE
AVIS
JUSTICES OF THE PEACE ACT
LOI SUR LES JUGES DE PAIX
Notice is hereby given that Robert Timothy Casey has ceased
to be a Justice of the Peace by operation of section 3 of the
Justices of the Peace Act, as he no longer resides in the
Northwest Territories.
Avis est donné par la présente que Robert Timothy Casey,
n’étant plus résident des Territoires du Nord-Ouest, a cessé
d’être juge de paix par l’effet de l’article 3 de la Loi sur les
juges de paix.
LOCAL AUTHORITIES ELECTIONS ACT
LOI SUR LES ÉLECTIONS DES
ADMINISTRATIONS LOCALES
Notice is hereby given that Dora Duncan has ceased to be a
Justice of the Peace by operation of section 18.1(4) of the
Local Authorities Elections Act, as she was elected as Chief
of the settlement council of Colville Lake, NT on June 1,
2001.
Avis est donné par la présente que Dora Duncan, ayant été
élue chef du conseil de localité de Colville Lake, T.N.-O. le
1er juin 2001, a cessé d’être un juge de paix par l’effet du
paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les élections des
administrations locales.
LOCAL AUTHORITIES ELECTIONS ACT
LOI SUR LES ÉLECTIONS DES
ADMINISTRATIONS LOCALES
Notice is hereby given that Lucy Jackson has ceased to be a
Justice of the Peace by operation of section 18.1(4) of the
Local Authorities Elections Act, as she was elected as a
member of the K’ásho Got’iné Charter Community Council
for Fort Good Hope in 2007.
Avis est donné par la présente que Lucy Jackson, ayant été
élue au conseil de communauté à charte de K’ásho Got’iné
pour Fort Good Hope en 2007, a cessé d’être un juge de paix
par l’effet du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les élections
des administrations locales.
190
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Volume 35, No. 8 / Volume 35, no 8
CHANGE OF NAME ACT / LOI SUR LE CHANGEMENT DE NOM
The following changes of names have been registered under the Change of Name Act and are hereby published in accordance with section 14 of that Act: /
Les changements de nom qui suivent ont été enregistrés en application de la Loi sur le changement de nom et sont, par les présentes, publiés en conformité avec l’article 14 de cette
loi.
FORMER SURNAME / GIVEN NAMES
ANCIEN NOM DE FAMILLE /
ANCIENS PRÉNOMS
DATE OF BIRTH
(dd/mm/yyyy) /
DATE DE
NAISSANCE
(jour/mois/année)
COMMUNITY OF
RESIDENCE /
COLLECTIVITÉ
OÙ LA PERSONNE
RÉSIDE
REVISED NAME
(SURNAME/GIVEN) /
NOUVEAU NOM
(NOM DE FAMILLE/PRÉNOMS)
EFFECTIVE DATE
(dd/mm/yyyy) /
DATE DE PRISE
D’EFFET
(jour/mois/année)
Mountain/Antoine
01/11/1949
Fort Good Hope
Mountain/Antoine Bear Rock
10/07/2014
Bilodeau, Alisa-Rose Constance
27/09/2012
Yellowknife
Fochuk/Alisa-Rose Constance
15/07/2014
Sultan/Soraya Gisele
03/12/1961
Yellowknife
Sultan/Sarah Giselle Soreiya
16/07/2014
191
Part I / Partie I
Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest
Volume 35, No. 8 / Volume 35, no 8
EVIDENCE ACT
LOI SUR LA PREUVE
Appointments and reappointments (R) of Commissioners for Oaths:
Nominations et renominations (R) de commissaires aux serments :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
ALLDRIDGE, Ferial (R)
ALLEN, Deborah Ann
AREY, Rita R (R)
BROWNING, Rosie J.
CAESAR, Karen L (R)
CROCKER, Darren Mark (R)
ELDER, Louise Mae
HEWLKO, Sonia Anna (R)
JONES, Kristy
KILPATRICK, Lana Marion
LEPAGE, Barbara Denise
MACKENZIE, Samantha (R)
SAVARD, Andree
WALKER, William Robert
WOLDUM, Kristen Phyllis (R)
Inuvik
Behchokö
Aklavik
Hay River
Fort Good Hope
Edmonton
Yellowknife
Yellowknife
Fort Smith
Inuvik
Yellowknife
Yellowknife
Behchokö
Yellowknife
Yellowknife
Appointments and reappointments (R) of Notaries Public:
Nominations et renominations (R) de notaires publics :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
CASH, Alan (R)
DAS, Malay
EGGENBERGER, Wendy Jeanne (R)
FORCADE, Lauri Anne
LEONARDIS, Dorothy Gail (R)
MATHESON, Kym Zoe (R)
MIRZA, Jasmin
MORLEY, Allison Emma
MOULD, Robin Anne (R)
ORLIAS, Ann Margaret
RIEGER, Heaven Elizabeth
RUIZ, Barbara Ann (R)
TEREPOSKY, Andrew
WALSH, Trudie A. (R)
Yellowknife
Hay River
Yellowknife
Inuvik
Yellowknife
Norman Wells
Yellowknife
Yellowknife
Yellowknife
Colville Lake
Yellowknife
Yellowknife
Yellowknife
Hay River
Revocation of Commissioners for Oath:
Révocation d’un commissaire aux serments :
a)
JACKSON, Elizabeth Jean
Yellowknife
Printed by
Territorial Printer, Northwest Territories
Yellowknife, N.W.T./2014©
Imprimé par
l’imprimeur territorial, Territoires du Nord-Ouest
Yellowknife (T. N.-O.)/2014©
192